-
ICON GAMING LTD - First Floor, Sheraton House, Lower Road, Chorleywood, Herts, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09427367
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- First Floor, Sheraton House
- Lower Road
- Chorleywood
- Herts
- WD3 5LH
- England First Floor, Sheraton House, Lower Road, Chorleywood, Herts, WD3 5LH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COLLINS, Kevin Mark
- KATRAVAS, Evgenios
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.02.2015
- Alter der Firma 2015-02-06 9 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Evgenios Katravas
- Mr Evgenios Katravas
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- MAGIK WAND LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-01
- Letzte Einreichung: 2023-05-18
-
ICON GAMING LTD Firmenbeschreibung
- ICON GAMING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09427367. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.02.2015 registriert. ICON GAMING LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MAGIK WAND LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über First Floor, Sheraton House erreicht werden.
Jetzt sichern ICON GAMING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Icon Gaming Ltd - First Floor, Sheraton House, Lower Road, Chorleywood, Herts, Grossbritannien
- 2015-02-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ICON GAMING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-18) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-17) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-05) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-11-05) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-05) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-10-26) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-09-03) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-28) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-06-06) - AP04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-11) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-10) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-09) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-09) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-09) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2018-01-29) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-10-15) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-07) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-07-29) - AA01
-
incorporation-company (2015-02-06) - NEWINC