-
PBH SURVEYS LIMITED - 4a Custance Walk, York, YO23 1BX, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09413859
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4a Custance Walk
- York
- YO23 1BX
- England 4a Custance Walk, York, YO23 1BX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BECKER, Cecil Adriaan
- CHILTON, Matthew Alistair
- KAY, Robert James
- MORROW, Callum Robert
- SMITH, Nathan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-30 9 Jahre
- SIC/NACE
- 71129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Matthew Alistair Chilton
- -
- Y&Sb Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-13
- Letzte Einreichung: 2023-01-30
-
PBH SURVEYS LIMITED Firmenbeschreibung
- PBH SURVEYS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09413859. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.01.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71129" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 4A Custance Walk erreicht werden.
Jetzt sichern PBH SURVEYS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pbh Surveys Limited - 4a Custance Walk, York, YO23 1BX, England, Grossbritannien
- 2015-01-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PBH SURVEYS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-person-director-company-with-change-date (2024-01-27) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2024-01-27) - PSC04
keyboard_arrow_right 2023
-
capital-return-purchase-own-shares (2023-12-06) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2023-11-01) - SH06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-10-09) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-01-04) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-13) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-05-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-07-31) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-07-26) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-07-26) - SH10
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-07-25) - SH10
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-07-25) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-19) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-18) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-cancellation-shares (2018-07-19) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-07-06) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-28) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-16) - CS01
-
resolution (2017-06-06) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-06-12) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-06-12) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-27) - AA
-
resolution (2017-11-02) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-11-02) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-11-02) - SH10
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-25) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-23) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-07-22) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-22) - AP01
-
incorporation-company (2015-01-30) - NEWINC