-
COOPLANDS KITCHEN LTD - Cooplands Bakery Victoria Mill Business Park, Wharf Road, Doncaster, DN1 2SX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09406750
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cooplands Bakery Victoria Mill Business Park
- Wharf Road
- Doncaster
- DN1 2SX
- England Cooplands Bakery Victoria Mill Business Park, Wharf Road, Doncaster, DN1 2SX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- STEEL, Angus Kennedy
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-26 9 Jahre
- SIC/NACE
- 10710
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Angus Kennedy Steel
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ALISON'S CAKES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-09
- Letzte Einreichung: 2020-01-26
-
COOPLANDS KITCHEN LTD Firmenbeschreibung
- COOPLANDS KITCHEN LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09406750. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.01.2015 registriert. COOPLANDS KITCHEN LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ALISON'S CAKES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10710" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Cooplands Bakery Victoria Mill Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern COOPLANDS KITCHEN LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cooplands Kitchen Ltd - Cooplands Bakery Victoria Mill Business Park, Wharf Road, Doncaster, DN1 2SX, Grossbritannien
- 2015-01-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COOPLANDS KITCHEN LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-05-18) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-19) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-04-06) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-04-07) - DISS40
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-06) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-21) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-04) - AP01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-06-08) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-08-20) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-20) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-10-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-08) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-06) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-06) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-14) - TM01
-
resolution (2016-06-10) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-18) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-10) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2015-02-13) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-21) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2015-05-22) - AP02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-27) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-04) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-06-11) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-12) - TM02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-27) - TM02
-
incorporation-company (2015-01-26) - NEWINC