-
OMEGA NEWCO SUB I LIMITED - 4650 Kingsgate Cascade Way, Oxford Business Park South, Oxford, Oxfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09402268
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4650 Kingsgate Cascade Way
- Oxford Business Park South
- Oxford
- Oxfordshire
- OX4 2SU 4650 Kingsgate Cascade Way, Oxford Business Park South, Oxford, Oxfordshire, OX4 2SU UK
Management
- Geschäftsführung
- HOWELL, Simon Paul
- HARRISON, Philip Michael
- WONG, Chen Vui
- Prokuristen
- LUDLOW, David Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-22 9 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ti Fluid Systems Plc
- Omega Acquisition Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- OMEGA HOLDCO I LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 549300NJWJDTVYRWH059
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-05
- Letzte Einreichung: 2023-01-22
-
OMEGA NEWCO SUB I LIMITED Firmenbeschreibung
- OMEGA NEWCO SUB I LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09402268. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.01.2015 registriert. OMEGA NEWCO SUB I LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen OMEGA HOLDCO I LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 4650 Kingsgate Cascade Way erreicht werden.
Jetzt sichern OMEGA NEWCO SUB I LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Omega Newco Sub I Limited - 4650 Kingsgate Cascade Way, Oxford Business Park South, Oxford, Oxfordshire, Grossbritannien
- 2015-01-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OMEGA NEWCO SUB I LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-01) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-06-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-09) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-08-09) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-12-04) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-18) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-06) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-28) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-09-25) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-29) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-10) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-10) - AP03
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-01-22) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-08-05) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-29) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-08) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-07-08) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-08) - TM01
-
resolution (2015-04-28) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-04-16) - SH01
-
capital-redomination-of-shares (2015-02-23) - SH14
-
resolution (2015-02-22) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2015-02-16) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-02-16) - CERTNM