-
DISPATER RESERVE POWER LTD - 6th Floor 33 Holborn, London, England, EC1N 2HT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09379623
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6th Floor 33 Holborn
- London
- England
- EC1N 2HT 6th Floor 33 Holborn, London, England, EC1N 2HT UK
Management
- Geschäftsführung
- SKINNER, Robert James
- FELLOWS, Edward William
- Prokuristen
- OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.01.2015
- Gelöscht am:
- 2021-09-28
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Tm Trading Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-25
- Letzte Einreichung: 2021-01-11
-
DISPATER RESERVE POWER LTD Firmenbeschreibung
- DISPATER RESERVE POWER LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09379623. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.01.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 6Th Floor 33 Holborn erreicht werden.
Jetzt sichern DISPATER RESERVE POWER LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dispater Reserve Power Ltd - 6th Floor 33 Holborn, London, England, EC1N 2HT, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DISPATER RESERVE POWER LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-10) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-24) - CS01
-
resolution (2020-01-10) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-07) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-05) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-04-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
legacy (2019-12-18) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-12-18) - SH19
-
legacy (2019-12-18) - CAP-SS
-
resolution (2019-12-18) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-17) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-04-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-16) - CS01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2019-01-03) - AP04
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-15) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-04-06) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-02-20) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-13) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-26) - AP03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-15) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-19) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-02-01) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-19) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-03-21) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-05-07) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-19) - TM02
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-02-05) - AA01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-05-31) - CH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-04) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-24) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-05) - TM02
-
resolution (2015-06-12) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-08) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-10-22) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-05) - AP03
-
resolution (2015-04-20) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-04-07) - SH01
-
memorandum-articles (2015-02-19) - MA
-
capital-allotment-shares (2015-02-02) - SH01
-
incorporation-company (2015-01-08) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-17) - MR01