-
SILVER BIOGAS LIMITED - Stanmore House, 64-68 Blackburn Street, Manchester, M26 2JS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09370190
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Stanmore House
- 64-68 Blackburn Street
- Manchester
- M26 2JS Stanmore House, 64-68 Blackburn Street, Manchester, M26 2JS UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-30 9 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark O’Dowd
- Mr Gordon Joseph Archer
- Ms Monika Kolarich
- Dr Eleanor Catherine Wicks
- Ms Monika Kolarich
- Mr Mark O’Dowd
- Mr Mark Anthony O'Dowd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-01-13
- Letzte Einreichung: 2017-12-30
-
SILVER BIOGAS LIMITED Firmenbeschreibung
- SILVER BIOGAS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09370190. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Die Firma kann schriftlich über Stanmore House erreicht werden.
Jetzt sichern SILVER BIOGAS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Silver Biogas Limited - Stanmore House, 64-68 Blackburn Street, Manchester, M26 2JS, Grossbritannien
- 2014-12-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SILVER BIOGAS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-02-19) - AM10
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2020-06-24) - AM22
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-07-10) - 600
-
court-order (2020-07-20) - OC
-
(2020-07-20) - ANNOTATION
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-01-25) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-07-05) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2019-07-05) - AM19
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-08) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-26) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-11) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-22) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-05) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-08-23) - AM03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-22) - TM01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-07-03) - AM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-26) - TM01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2018-09-07) - AM07
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-10) - MR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-14) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-13) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-09-30) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-11) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-12-06) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-04-22) - SH01
-
resolution (2015-04-16) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-19) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-30) - NEWINC