-
QUARRINGTON RENEWABLE GAS LTD - Suite 5, 2nd Floor Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09366096
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 5, 2nd Floor Regent Centre
- Gosforth
- Newcastle Upon Tyne
- NE3 3LS Suite 5, 2nd Floor Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS UK
Management
- Geschäftsführung
- JOHNSON, Philip David
- SPRING, Timothy Rodney
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.12.2014
- Gelöscht am:
- 2022-04-12
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sqn Afif (Amber) Limited
- -
- Quarrington Farms Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-01-06
- Letzte Einreichung: 2018-12-23
-
QUARRINGTON RENEWABLE GAS LTD Firmenbeschreibung
- QUARRINGTON RENEWABLE GAS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09366096. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite 5, 2Nd Floor Regent Centre erreicht werden.
Jetzt sichern QUARRINGTON RENEWABLE GAS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Quarrington Renewable Gas Ltd - Suite 5, 2nd Floor Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS, Grossbritannien
- 2014-12-23
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QUARRINGTON RENEWABLE GAS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-02-16) - DS01
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2022-01-12) - AM23
-
gazette-dissolved-liquidation (2022-04-12) - GAZ2
-
restoration-order-of-court (2022-12-30) - AC92
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-02-10) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2021-06-22) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-08-26) - AM10
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-02-04) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-08-24) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2020-05-21) - AM19
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-05-03) - AA
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2019-09-27) - AM06
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2019-09-20) - AM02
-
liquidation-in-administration-proposals (2019-09-09) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-31) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2019-07-30) - AM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-04) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-03) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-03) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-23) - PSC07
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-04-06) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-03-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-08) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-13) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-24) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-24) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-12-08) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-29) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-29) - AA01
-
capital-allotment-shares (2015-04-29) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-04-29) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-04-29) - SH02
-
resolution (2015-04-29) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-23) - NEWINC