-
ALLIED PROPERTIES (LONDON) LTD - 22 Broadlands Avenue, London, SW16 1NA, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09344596
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 22 Broadlands Avenue
- London
- SW16 1NA
- England 22 Broadlands Avenue, London, SW16 1NA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AFREH POKU, Yaw
- ASANTE-CROMPTON, Joyce
- ODURO, Abigail
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-08 9 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Cynthia Appiagyei
- -
- -
- Mrs Joyce Asante-Crompton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-16
- Letzte Einreichung: 2023-03-02
-
ALLIED PROPERTIES (LONDON) LTD Firmenbeschreibung
- ALLIED PROPERTIES (LONDON) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09344596. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 22 Broadlands Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern ALLIED PROPERTIES (LONDON) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Allied Properties (London) Ltd - 22 Broadlands Avenue, London, SW16 1NA, England, Grossbritannien
- 2014-12-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALLIED PROPERTIES (LONDON) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-03-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-02-09) - AA
-
liquidation-receiver-cease-to-act-receiver (2023-01-10) - RM02
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-11-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-11-12) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-11-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-27) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-06-24) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-06-23) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-05-24) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-05-17) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-16) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-06-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-receiver-appointment-of-receiver (2021-07-20) - RM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-05-02) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2020-03-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-18) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-18) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-10-16) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-18) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-02-17) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-29) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-19) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-24) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-04) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-28) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-08) - NEWINC