-
ZODIAC SEVEN LIMITED - 135 Bishopsgate, London, EC2M 3TP, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09338396
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 135 Bishopsgate
- London
- EC2M 3TP
- England 135 Bishopsgate, London, EC2M 3TP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- STEWART, Garry Hunter
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-03 9 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Elliot Waxman
- Mrs Tracy Waxman
- Tp Icap Emea Investments Limited
- -
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-12-17
- Letzte Einreichung: 2021-12-03
-
ZODIAC SEVEN LIMITED Firmenbeschreibung
- ZODIAC SEVEN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09338396. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 135 Bishopsgate erreicht werden.
Jetzt sichern ZODIAC SEVEN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Zodiac Seven Limited - 135 Bishopsgate, London, EC2M 3TP, England, Grossbritannien
- 2014-12-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ZODIAC SEVEN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-03-21) - LIQ01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-04-28) - TM01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-01-04) - 600
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-30) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-15) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-08) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-11-30) - PSC07
-
resolution (2021-12-31) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-08) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-11-30) - PSC02
-
resolution (2021-12-07) - RESOLUTIONS
-
resolution (2021-12-03) - RESOLUTIONS
-
legacy (2021-12-03) - CAP-SS
-
legacy (2021-12-03) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-12-03) - SH19
-
memorandum-articles (2021-12-07) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-17) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-07-17) - TM02
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-02-15) - SH01
-
capital-allotment-shares (2019-02-26) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-05) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-08) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-12) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-11) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-11) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-05) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-12) - TM01
-
capital-allotment-shares (2018-01-24) - SH01
-
resolution (2018-01-23) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-12-15) - PSC04
-
capital-allotment-shares (2017-08-22) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-15) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-20) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-24) - TM02
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-20) - AAMD
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-13) - AP01
-
resolution (2017-07-26) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-24) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-15) - CS01
-
resolution (2016-12-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-11-10) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-23) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-01-19) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-07-17) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-07-17) - SH01
-
resolution (2015-07-21) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-07-21) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-10) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-11-02) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-03) - NEWINC