-
TEC CRE8 LTD - 5 The Barns Mill Lane, Snelson, Macclesfield, SK11 9BN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09327776
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 The Barns Mill Lane
- Snelson
- Macclesfield
- SK11 9BN
- England 5 The Barns Mill Lane, Snelson, Macclesfield, SK11 9BN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOOLEY, Paul Christopher
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-26 9 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Hooley
- -
- Mr Duncan Kevin Phillip Godwin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-02-20
- Letzte Einreichung: 2024-02-06
-
TEC CRE8 LTD Firmenbeschreibung
- TEC CRE8 LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09327776. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.11.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 5 The Barns Mill Lane erreicht werden.
Jetzt sichern TEC CRE8 LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tec Cre8 Ltd - 5 The Barns Mill Lane, Snelson, Macclesfield, SK11 9BN, Grossbritannien
- 2014-11-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TEC CRE8 LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-01-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-02-07) - CS01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2024-04-23) - LIQ02
-
resolution (2024-04-23) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2024-04-23) - 600
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-17) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-17) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-17) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2021-02-12) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-17) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-26) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-06) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-10-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-17) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-24) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-15) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-13) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-03-01) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-04-12) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-04-05) - DISS16(SOAS)
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-11-26) - NEWINC