-
ANWOOD CONSTRUCTION LTD - Suite 5, 2nd Floor Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09321474
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 5, 2nd Floor Regent Centre
- Gosforth
- Newcastle Upon Tyne
- NE3 3LS Suite 5, 2nd Floor Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS UK
Management
- Geschäftsführung
- LYALL, Shaun
- WHARTON, Ritchie
- WILKINSON, Dale
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.11.2014
- Gelöscht am:
- 2021-12-02
- SIC/NACE
- 43320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-04
- Letzte Einreichung: 2018-11-20
-
ANWOOD CONSTRUCTION LTD Firmenbeschreibung
- ANWOOD CONSTRUCTION LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09321474. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.11.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43320" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite 5, 2Nd Floor Regent Centre erreicht werden.
Jetzt sichern ANWOOD CONSTRUCTION LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Anwood Construction Ltd - Suite 5, 2nd Floor Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ANWOOD CONSTRUCTION LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-09-02) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-12-02) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-02-14) - TM02
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-10) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-09-09) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-09) - 600
-
resolution (2019-09-09) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-18) - CS01
-
resolution (2019-01-17) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-01-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-22) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-24) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2018-01-25) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-10-15) - PSC08
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-30) - AA
-
resolution (2018-01-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-21) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-17) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-05) - AP01
-
resolution (2015-03-03) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-03-03) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-03-03) - SH10
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-05-13) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-16) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-12-15) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-15) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-15) - AP03
-
incorporation-company (2014-11-20) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-27) - TM01