-
DAMOCO HOLDCO LIMITED - Aurora House Deltic Avenue, Rooksley, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09316946
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Aurora House Deltic Avenue
- Rooksley
- Milton Keynes
- Buckinghamshire
- MK13 8LW Aurora House Deltic Avenue, Rooksley, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK13 8LW UK
Management
- Geschäftsführung
- MCFARLANE, Jeffrey James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-18 9 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Matthew Robinson Riley
- Peter Adam Daiches Dubens
- Ian Patrick Pilgrim
- Robert Paul Harold Stevenson
- Atlanta Bidco Limited
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-30
- Letzte Einreichung: 2021-01-16
-
DAMOCO HOLDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- DAMOCO HOLDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09316946. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.11.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Aurora House Deltic Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern DAMOCO HOLDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Damoco Holdco Limited - Aurora House Deltic Avenue, Rooksley, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2014-11-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAMOCO HOLDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
gazette-notice-compulsory (2022-01-04) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-02-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-05-13) - AA
-
resolution (2021-08-12) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-08-12) - MA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-19) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-23) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-16) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-29) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-30) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-29) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-29) - PSC02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-29) - MR04
-
capital-return-purchase-own-shares-treasury-capital-date (2018-08-31) - SH03
-
capital-allotment-shares (2018-08-15) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-07-31) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-07-30) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-07-24) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-08-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-07-05) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-17) - MR01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-03-02) - RP04
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-03-02) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-21) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-29) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-04-16) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-03) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-03-02) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-02) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-03-02) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-03-02) - SH08
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-11-18) - NEWINC