-
VHS (RETAIL) LIMITED - C/O Begbies Traynor, 340 Deansgate, Manchester, M3 4LY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09308568
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Begbies Traynor
- 340 Deansgate
- Manchester
- M3 4LY C/O Begbies Traynor, 340 Deansgate, Manchester, M3 4LY UK
Management
- Geschäftsführung
- CHESTERMAN, Edward John
- MARKHAM, Nicholas Francis
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-13 9 Jahre
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr David Christopher Chance
- Mr Ian Christopher West
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- BEETAMAX PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-08-31
- Letzte Einreichung: 2021-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-27
- Letzte Einreichung: 2021-11-13
-
VHS (RETAIL) LIMITED Firmenbeschreibung
- VHS (RETAIL) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09308568. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.11.2014 registriert. VHS (RETAIL) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BEETAMAX PROFESSIONAL SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Begbies Traynor erreicht werden.
Jetzt sichern VHS (RETAIL) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vhs (Retail) Limited - C/O Begbies Traynor, 340 Deansgate, Manchester, M3 4LY, Grossbritannien
- 2014-11-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VHS (RETAIL) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2024-04-13) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-04-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
resolution (2022-02-16) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-02-16) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-02-16) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-02-24) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-09-24) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2021-10-05) - CERTNM
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-11-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-08-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-14) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-14) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-13) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-09) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-09) - AR01
-
resolution (2015-03-09) - RESOLUTIONS
-
legacy (2015-03-09) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2015-03-09) - SH19
-
legacy (2015-03-09) - CAP-SS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-03) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-03-03) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-02) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-23) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-11-13) - NEWINC