-
LAMBERT PERRIN LIQUIDITY PLC - C/O Quantuma Llp High Holborn House, 52-54 High Holborn, London, WC1V 6RL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09292808
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Quantuma Llp High Holborn House
- 52-54 High Holborn
- London
- WC1V 6RL C/O Quantuma Llp High Holborn House, 52-54 High Holborn, London, WC1V 6RL UK
Management
- Geschäftsführung
- ADCREDO SERVICES LIMITED
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- plc
- Gründungsdatum
- 03.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-03 9 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Lambert Perrin Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- HJ LIQUID ASSETS PLC
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800HK1SJFWZ6QCS85
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-05-31
- Letzte Einreichung: 2017-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-17
- Letzte Einreichung: 2018-11-03
-
LAMBERT PERRIN LIQUIDITY PLC Firmenbeschreibung
- LAMBERT PERRIN LIQUIDITY PLC ist eine in Grossbritannien als plc registrierte Firma mit der Register-Nr. 09292808. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.11.2014 registriert. LAMBERT PERRIN LIQUIDITY PLC hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HJ LIQUID ASSETS PLC ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Quantuma Llp High Holborn House erreicht werden.
Jetzt sichern LAMBERT PERRIN LIQUIDITY PLC HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lambert Perrin Liquidity Plc - C/O Quantuma Llp High Holborn House, 52-54 High Holborn, London, WC1V 6RL, Grossbritannien
- 2014-11-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LAMBERT PERRIN LIQUIDITY PLC aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-08-11) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-08-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-19) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-06-17) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-17) - 600
-
resolution (2019-06-17) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-14) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2019-02-14) - AP02
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-30) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-12-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-03) - TM01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-12-14) - AP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-03) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-25) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-15) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-11) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-06) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-26) - AP01
-
resolution (2016-05-25) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-05-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
auditors-report (2015-01-28) - AUDR
-
accounts-balance-sheet (2015-01-28) - BS
-
re-registration-memorandum-articles (2015-01-28) - MAR
-
resolution (2015-01-28) - RESOLUTIONS
-
reregistration-private-to-public-company (2015-01-28) - RR01
-
auditors-statement (2015-01-28) - AUDS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-05) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-15) - AR01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2015-12-23) - RP04
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-01-28) - AP04
-
certificate-re-registration-private-to-public-limited-company (2015-01-28) - CERT5
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-11-03) - NEWINC