-
DYER & BUTLER 2014 LIMITED - Abel Smith House, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09286713
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Abel Smith House
- Gunnels Wood Road
- Stevenage
- Hertfordshire
- SG1 2ST
- England Abel Smith House, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2ST, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ARNOLD, James Michael
- DAVIES, John Harold
- WINNICOTT, James Robert
- FINDLAY, Andrew Robert
- Prokuristen
- COOPER, William James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.10.2014
- Gelöscht am:
- 2023-04-04
- SIC/NACE
- 42990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- M Group Services Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-12
- Letzte Einreichung: 2021-10-29
-
DYER & BUTLER 2014 LIMITED Firmenbeschreibung
- DYER & BUTLER 2014 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09286713. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.10.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Abel Smith House erreicht werden.
Jetzt sichern DYER & BUTLER 2014 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dyer & Butler 2014 Limited - Abel Smith House, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DYER & BUTLER 2014 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-12-24) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-02-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-22) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-12-24) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-23) - TM02
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-12-18) - SH08
-
resolution (2019-12-18) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-01-03) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-11) - CH01
-
resolution (2018-08-22) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-05) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-07) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-06) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-06) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-06) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-27) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-17) - MR01
-
resolution (2017-03-14) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-06-02) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-03) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-16) - MR01
-
legacy (2017-02-23) - RP04CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-24) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-02-28) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-12-22) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-09-14) - AA
-
legacy (2016-11-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-12-19) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-12-19) - SH08
-
capital-allotment-shares (2014-12-19) - SH01
-
resolution (2014-12-17) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-12-09) - MR01
-
incorporation-company (2014-10-29) - NEWINC