-
TWO DOT ZERO LIMITED - 45 Frederick Street, Birmingham, B1 3HN, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09225379
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 45 Frederick Street
- Birmingham
- B1 3HN
- England 45 Frederick Street, Birmingham, B1 3HN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- THOMAS, Nadine Ann
- VERRALL, Stephen John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-18 9 Jahre
- SIC/NACE
- 90030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Stephen John Verrall
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GREEN ROOM DESIGN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-02
- Letzte Einreichung: 2022-09-18
-
TWO DOT ZERO LIMITED Firmenbeschreibung
- TWO DOT ZERO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09225379. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.09.2014 registriert. TWO DOT ZERO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GREEN ROOM DESIGN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "90030" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 45 Frederick Street erreicht werden.
Jetzt sichern TWO DOT ZERO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Two Dot Zero Limited - 45 Frederick Street, Birmingham, B1 3HN, England, Grossbritannien
- 2014-09-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TWO DOT ZERO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-16) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2022-03-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-20) - CS01
-
change-of-name-notice (2021-01-25) - CONNOT
-
resolution (2021-01-25) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
memorandum-articles (2020-04-27) - MA
-
resolution (2020-04-27) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-03-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-21) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-02) - TM01
-
memorandum-articles (2020-12-03) - MA
-
resolution (2020-11-27) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-11-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-05) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-05) - PSC07
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-11-20) - SH08
-
resolution (2019-11-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-20) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-20) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-16) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-02-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-02-18) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-07) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-24) - AD01
-
resolution (2016-07-29) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-09-16) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-23) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-02-03) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-of-name-notice (2014-10-13) - CONNOT
-
capital-allotment-shares (2014-11-11) - SH01
-
resolution (2014-11-11) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-10) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-21) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-13) - CERTNM
-
incorporation-company (2014-09-18) - NEWINC