-
MTD ELITE SERVICES LIMITED - C/O MAZARS LLP, Tower Bridge House St Katharine's Way, London, E1W 1DD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09222376
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O MAZARS LLP
- Tower Bridge House St Katharine's Way
- London
- E1W 1DD C/O MAZARS LLP, Tower Bridge House St Katharine's Way, London, E1W 1DD UK
Management
- Geschäftsführung
- DIXON, Matthew Terrence
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Matthew Terrence Dixon
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- BOILERS ON FINANCE INSTALLATIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-06-30
- Letzte Einreichung: 2017-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-27
- Letzte Einreichung: 2018-03-13
-
MTD ELITE SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- MTD ELITE SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09222376. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.09.2014 registriert. MTD ELITE SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BOILERS ON FINANCE INSTALLATIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Mazars Llp erreicht werden.
Jetzt sichern MTD ELITE SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mtd Elite Services Limited - C/O MAZARS LLP, Tower Bridge House St Katharine's Way, London, E1W 1DD, Grossbritannien
- 2014-09-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MTD ELITE SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-29) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-11-20) - NDISC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-12) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-09-05) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-09-05) - 600
-
resolution (2018-09-05) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-31) - PSC02
-
resolution (2018-03-13) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-11) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-11) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-11) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-03) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-31) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-31) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-01-31) - AP02
-
capital-allotment-shares (2018-01-31) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-01-24) - SH01
-
resolution (2018-01-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-21) - AA
-
resolution (2017-05-10) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-13) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-16) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-25) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-27) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-14) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-09-17) - NEWINC