-
GOODLIFE PROJECTS LIMITED - 4th, Floor Cathedral Buildings, Dean Street, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09219948
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th
- Floor Cathedral Buildings
- Dean Street
- Newcastle Upon Tyne
- NE1 1PG 4th, Floor Cathedral Buildings, Dean Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PG UK
Management
- Geschäftsführung
- BOUD, Jonathan Edward Donnan
- POTTER, Alexander William Jack
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.09.2014
- Gelöscht am:
- 2020-09-01
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alexander William Jack Potter
- Mr Jonathan Edward Donnan Boud
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-06-30
- Letzte Einreichung: 2017-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-09-16
-
GOODLIFE PROJECTS LIMITED Firmenbeschreibung
- GOODLIFE PROJECTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09219948. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.09.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4Th erreicht werden.
Jetzt sichern GOODLIFE PROJECTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Goodlife Projects Limited - 4th, Floor Cathedral Buildings, Dean Street, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GOODLIFE PROJECTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-06-01) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-09-01) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-31) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-25) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-01-16) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-01-16) - 600
-
resolution (2019-01-16) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-03) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-19) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-19) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-21) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-12) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-09-12) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-17) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-21) - CH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-10-20) - SH08
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-09-16) - NEWINC