-
JOHOCO 2029 LIMITED - Suites G & H Ground Floor Steam Mill, Steam Mill Street, Chester, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09211866
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suites G & H Ground Floor Steam Mill
- Steam Mill Street
- Chester
- Cheshire
- CH3 5AN Suites G & H Ground Floor Steam Mill, Steam Mill Street, Chester, Cheshire, CH3 5AN UK
Management
- Geschäftsführung
- BACON, Robert Alan
- CAMPBELL, Paul Adam
- KEMP-WELCH, Peter John
- MCDONNELL, Neil Edward
- POWELL, Matthew David
- WELSH, John William
- Prokuristen
- MCDONNELL, Marita
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-10 9 Jahre
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Neil Edward Mcdonnell
- Piper Nominees Iv Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-24
- Letzte Einreichung: 2021-09-10
-
JOHOCO 2029 LIMITED Firmenbeschreibung
- JOHOCO 2029 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09211866. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.09.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Suites G & H Ground Floor Steam Mill erreicht werden.
Jetzt sichern JOHOCO 2029 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Johoco 2029 Limited - Suites G & H Ground Floor Steam Mill, Steam Mill Street, Chester, Cheshire, Grossbritannien
- 2014-09-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JOHOCO 2029 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-05-28) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-01-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-06-18) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-01-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-03) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-02-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-04-04) - SH01
-
resolution (2016-04-19) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2016-04-19) - MA
-
resolution (2016-09-05) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-09-23) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2016-10-12) - SH06
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-02) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-02) - CH01
-
memorandum-articles (2016-09-05) - MA
-
resolution (2016-09-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-10) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-09) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-09) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-03-16) - CH01
-
resolution (2015-04-30) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-09-10) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-11) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-17) - AD01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2014-09-17) - AP02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-25) - TM01
-
resolution (2014-10-28) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-10-30) - SH02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-10-31) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-31) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-11-11) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-10-30) - AA01