-
OPTIMUM DATA CENTRES LIMITED - Begbies Traynor (Central) Llp, 5 Prospect House, Meridians Cross, Ocean Way, Southampton, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09191119
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Begbies Traynor (Central) Llp, 5 Prospect House
- Meridians Cross
- Ocean Way
- Southampton
- SO14 3TJ Begbies Traynor (Central) Llp, 5 Prospect House, Meridians Cross, Ocean Way, Southampton, SO14 3TJ UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.08.2014
- Alter der Firma 2014-08-28 9 Jahre
- SIC/NACE
- 99000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Paula Mcquillan
- Mrs Paula Mcquillan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-07
- Letzte Einreichung: 2019-10-26
-
OPTIMUM DATA CENTRES LIMITED Firmenbeschreibung
- OPTIMUM DATA CENTRES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09191119. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.08.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99000" registriert. Die Firma kann schriftlich über Begbies Traynor (Central) Llp, 5 Prospect House erreicht werden.
Jetzt sichern OPTIMUM DATA CENTRES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Optimum Data Centres Limited - Begbies Traynor (Central) Llp, 5 Prospect House, Meridians Cross, Ocean Way, Southampton, Grossbritannien
- 2014-08-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OPTIMUM DATA CENTRES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-12-07) - LIQ02
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-20) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-05-14) - DISS16(SOAS)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-12-02) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-12-07) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-09-07) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-05-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-05-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-26) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-05-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-28) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-17) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-11) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-11) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-16) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-26) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-22) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-01) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-08-28) - NEWINC
-
resolution (2014-10-29) - RESOLUTIONS