-
CYPRESS GARDENS BRAINTREE LIMITED - 900 The Crescent, Colchester Business Park, Colchester, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09190865
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 900 The Crescent
- Colchester Business Park
- Colchester
- Essex
- CO4 9YQ
- England 900 The Crescent, Colchester Business Park, Colchester, Essex, CO4 9YQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HEASMAN, Derek Mark
- RICHARDS, Philip Brian
- WALDON, Victoria Frances Ann
- Prokuristen
- RICHARDS, Philip Brian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.08.2014
- Gelöscht am:
- 2023-06-27
- SIC/NACE
- 87100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Provide Community Interest Company
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- CYPRUS GARDENS BRAINTREE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-11
- Letzte Einreichung: 2022-08-28
-
CYPRESS GARDENS BRAINTREE LIMITED Firmenbeschreibung
- CYPRESS GARDENS BRAINTREE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09190865. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 28.08.2014 registriert. CYPRESS GARDENS BRAINTREE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CYPRUS GARDENS BRAINTREE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 900 The Crescent erreicht werden.
Jetzt sichern CYPRESS GARDENS BRAINTREE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cypress Gardens Braintree Limited - 900 The Crescent, Colchester Business Park, Colchester, Essex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CYPRESS GARDENS BRAINTREE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-03-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2023-02-28) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-01-27) - AA
-
legacy (2022-01-27) - PARENT_ACC
-
legacy (2022-01-27) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-01-27) - AGREEMENT2
-
legacy (2022-01-04) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-07) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-08) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-04-16) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-07) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-17) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-01-08) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-05) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-07) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-07) - PSC02
-
resolution (2020-01-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-28) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-07) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2016-11-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-22) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-09) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-01-05) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-02) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-09-24) - AA01
-
incorporation-company (2014-08-28) - NEWINC