-
NBCMH HOLDINGS LIMITED - The Bower, 4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Hayes, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09189333
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Bower, 4 Roundwood Avenue
- Stockley Park
- Uxbridge
- Hayes
- UB11 1AF
- United Kingdom The Bower, 4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Hayes, UB11 1AF, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- WARD, Philip John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.08.2014
- Alter der Firma 2014-08-28 9 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Envista Holdings Corporation
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AGHOCO 1251 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-20
- Letzte Einreichung: 2021-06-06
-
NBCMH HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- NBCMH HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09189333. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.08.2014 registriert. NBCMH HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AGHOCO 1251 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Bower, 4 Roundwood Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern NBCMH HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nbcmh Holdings Limited - The Bower, 4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Hayes, Grossbritannien
- 2014-08-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NBCMH HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-18) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-08-10) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-10) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-23) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-02-26) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-26) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-06) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-05-10) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-05-10) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-10) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
legacy (2017-06-08) - CAP-SS
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-01) - CS01
-
legacy (2017-06-08) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2017-06-08) - SH19
-
resolution (2017-06-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-25) - AR01
-
legacy (2015-03-20) - SH20
-
legacy (2015-03-20) - CAP-SS
-
resolution (2015-03-20) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-02) - TM01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2015-03-20) - SH19
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-17) - AD01
-
incorporation-company (2014-08-28) - NEWINC
-
change-of-name-notice (2014-10-01) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-01) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-17) - AP01
-
capital-redomination-of-shares (2014-10-24) - SH14
-
capital-reduction-of-capital-redomination (2014-10-24) - SH15
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-10-28) - AA01
-
capital-statement-directors-reduction-of-capital-following-redomination (2014-10-24) - SH18
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-03) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-11) - AP01
-
resolution (2014-10-24) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-17) - TM02