-
KENDALLCO LIMITED - Focus 31 West Wing Cleveland Road, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09176418
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Focus 31 West Wing Cleveland Road
- Hemel Hempstead Industrial Estate
- Hemel Hempstead
- Hertfordshire
- HP2 7BW Focus 31 West Wing Cleveland Road, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7BW UK
Management
- Geschäftsführung
- BURNS, Stephen
- KEEN, Laurence Brian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.08.2014
- Alter der Firma 2014-08-14 9 Jahre
- SIC/NACE
- 93199
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Kanyeco Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 21380031X9W7UP1K4W95
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-21
- Letzte Einreichung: 2021-06-07
-
KENDALLCO LIMITED Firmenbeschreibung
- KENDALLCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09176418. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.08.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93199" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Focus 31 West Wing Cleveland Road erreicht werden.
Jetzt sichern KENDALLCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kendallco Limited - Focus 31 West Wing Cleveland Road, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2014-08-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KENDALLCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
legacy (2021-04-21) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-04-21) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-04-21) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-06-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-10) - CS01
-
legacy (2020-02-13) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-02-13) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-02-13) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-07) - CS01
-
legacy (2019-03-21) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-03-21) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-03-21) - AGREEMENT2
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-07) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-07) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-07) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-04-03) - AA
-
legacy (2018-03-12) - PARENT_ACC
-
legacy (2018-02-28) - AGREEMENT2
-
legacy (2018-02-28) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2017
-
legacy (2017-11-21) - SH20
-
capital-allotment-shares (2017-11-23) - SH01
-
legacy (2017-11-21) - CAP-SS
-
resolution (2017-11-21) - RESOLUTIONS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2017-12-07) - SH19
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2017-07-19) - AA
-
legacy (2017-07-04) - AGREEMENT2
-
legacy (2017-07-04) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-07) - CS01
-
legacy (2017-07-14) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-09-22) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-02-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-12) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-03-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-12) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-01-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-08-14) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-04) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-11) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-16) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-09-11) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-11) - AP01
-
resolution (2014-09-17) - RESOLUTIONS