-
HAMLEY PROPERTY (6) LIMITED - 5 Stirling Court, Stirling Way, Borehamwood, WD6 2FX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09136729
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Stirling Court
- Stirling Way
- Borehamwood
- WD6 2FX
- England 5 Stirling Court, Stirling Way, Borehamwood, WD6 2FX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- DIAMANT, Adam
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-18 9 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas Fisher
- Mr Lloyd Andrew Gold
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-30
- Letzte Einreichung: 2021-03-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-12
- Letzte Einreichung: 2021-05-29
-
HAMLEY PROPERTY (6) LIMITED Firmenbeschreibung
- HAMLEY PROPERTY (6) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09136729. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.07.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 5 Stirling Court erreicht werden.
Jetzt sichern HAMLEY PROPERTY (6) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hamley Property (6) Limited - 5 Stirling Court, Stirling Way, Borehamwood, WD6 2FX, Grossbritannien
- 2014-07-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HAMLEY PROPERTY (6) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-09) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-10-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-14) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-01-27) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-05) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-05) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-03) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-12-07) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-10-08) - GAZ1
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-04) - MR04
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-06-15) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-12) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-28) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-03) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-27) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-03) - PSC01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-02-14) - AP03
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-28) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-24) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-24) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-06) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-03) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-03) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-03-03) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-04) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-08) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-16) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-25) - TM01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-19) - AAMD
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-16) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-07-18) - NEWINC