-
TAYLOR - ROWLES LTD - Unit 4 Madison Court, George Mann Road, Leeds, LS10 1DX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09130234
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 4 Madison Court
- George Mann Road
- Leeds
- LS10 1DX Unit 4 Madison Court, George Mann Road, Leeds, LS10 1DX UK
Management
- Geschäftsführung
- TAYLOR, Daryl George
- Prokuristen
- TAYLOR, Daryl George
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-14 9 Jahre
- SIC/NACE
- 45320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Daryl George Taylor
- Mr Simon Taylor
- Mr Simon Taylor
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- MOTO BERAZZI LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-28
- Letzte Einreichung: 2021-07-14
-
TAYLOR - ROWLES LTD Firmenbeschreibung
- TAYLOR - ROWLES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09130234. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.07.2014 registriert. TAYLOR - ROWLES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MOTO BERAZZI LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45320" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 4 Madison Court erreicht werden.
Jetzt sichern TAYLOR - ROWLES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Taylor - Rowles Ltd - Unit 4 Madison Court, George Mann Road, Leeds, LS10 1DX, Grossbritannien
- 2014-07-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TAYLOR - ROWLES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-09-02) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-09) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-08-04) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-08-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
resolution (2022-06-20) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-06-20) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-06-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-23) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-23) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-04) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-29) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-17) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-12-02) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-12-03) - DISS40
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-25) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-03-05) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-26) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-30) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-23) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-23) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-10-10) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-27) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-08) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-15) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-15) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-08-15) - PSC09
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-27) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-07-18) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-15) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-07-14) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-17) - AP01