-
BRIARS FARM LIMITED - Maltravers House, Petters Way, Yeovil, Somerset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09117937
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Maltravers House
- Petters Way
- Yeovil
- Somerset
- BA20 1SH Maltravers House, Petters Way, Yeovil, Somerset, BA20 1SH UK
Management
- Geschäftsführung
- WINSTONE, George James
- WINSTONE, Peter George
- WINSTONE, Wendy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-07 9 Jahre
- SIC/NACE
- 01410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Peter George Winstone
- Wendy Winstone
- Mr George James Winstone
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-25
- Letzte Einreichung: 2023-08-11
-
BRIARS FARM LIMITED Firmenbeschreibung
- BRIARS FARM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09117937. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.07.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01410" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Maltravers House erreicht werden.
Jetzt sichern BRIARS FARM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Briars Farm Limited - Maltravers House, Petters Way, Yeovil, Somerset, Grossbritannien
- 2014-07-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRIARS FARM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-08-18) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-08-18) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2023-09-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-26) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-08-25) - PSC04
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-23) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-25) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-25) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-08-25) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-15) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-15) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-08-14) - SH08
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2018-01-12) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-25) - AA
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-10-03) - SH19
-
legacy (2018-10-03) - CAP-SS
-
legacy (2018-10-03) - SH20
-
resolution (2018-10-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-08) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-21) - PSC07
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-19) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-08-22) - SH01
-
resolution (2016-08-17) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-04) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-10-28) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-10-28) - SH08
-
resolution (2014-10-28) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-10-27) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-14) - MR01
-
incorporation-company (2014-07-07) - NEWINC