-
PROJECT 92 LIMITED - St Andrews Chambers, 21 Albert Square, Manchester, M2 5PE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09112699
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- St Andrews Chambers
- 21 Albert Square
- Manchester
- M2 5PE
- United Kingdom St Andrews Chambers, 21 Albert Square, Manchester, M2 5PE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BECKHAM, David Robert Joseph
- BUTT, Nicholas
- CHAN, Lay Hoon
- GIGGS, Ryan Joseph
- NEVILLE, Gary Alexander
- NEVILLE, Philip John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-02 9 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Eng Hock Lim
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800SFYPX2L7HEOH24
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-16
- Letzte Einreichung: 2023-07-02
-
PROJECT 92 LIMITED Firmenbeschreibung
- PROJECT 92 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09112699. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.07.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über St Andrews Chambers erreicht werden.
Jetzt sichern PROJECT 92 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Project 92 Limited - St Andrews Chambers, 21 Albert Square, Manchester, M2 5PE, Grossbritannien
- 2014-07-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROJECT 92 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-03-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-07-03) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-04-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-09) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-08-16) - MR01
-
memorandum-articles (2022-09-23) - MA
-
resolution (2022-09-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-07-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-18) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-06-14) - SH08
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-31) - CH01
-
resolution (2019-04-25) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-02-13) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-02-13) - PSC08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-04) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-10-11) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-22) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-11) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-16) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-17) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-05-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-14) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-01-26) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-14) - TM01
-
resolution (2015-01-26) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-26) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-01-26) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-26) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-01-26) - SH08
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-08-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-07-02) - NEWINC