-
PACKETTS HOLDINGS LIMITED - Salts Wharf, Ashley Lane, Shipley, BD17 7DB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09107369
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Salts Wharf
- Ashley Lane
- Shipley
- BD17 7DB Salts Wharf, Ashley Lane, Shipley, BD17 7DB UK
Management
- Geschäftsführung
- SUGDEN, Marshall John
- HANNAN, Edward George Fitzgerald
- HARDIE, Alistair John David
- LALLEY, Graeme Neal
- Prokuristen
- SAEIDI, Anna
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-30 9 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Jgl Bidco 1 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-22
- Letzte Einreichung: 2020-12-08
-
PACKETTS HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- PACKETTS HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09107369. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.06.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Salts Wharf erreicht werden.
Jetzt sichern PACKETTS HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Packetts Holdings Limited - Salts Wharf, Ashley Lane, Shipley, BD17 7DB, Grossbritannien
- 2014-06-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PACKETTS HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-02-11) - MR04
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-02-11) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-11) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2021-02-11) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-11) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-02-11) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-15) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-11) - PSC02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-09-15) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-27) - CH01
-
memorandum-articles (2021-02-23) - MA
-
resolution (2021-02-23) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-22) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-02-22) - SH08
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-09-15) - AP03
keyboard_arrow_right 2020
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2020-11-10) - RP04CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-03-06) - SH08
-
resolution (2020-03-06) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-12) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-09) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-01) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-08) - CS01
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2020-12-21) - RP04AR01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-01) - TM01
-
confirmation-statement (2017-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-10-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-15) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-14) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-13) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-10) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-10) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-08-11) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-08-11) - AA01
-
incorporation-company (2014-06-30) - NEWINC