-
VISUALSOFT HOLDINGS 4 LIMITED - Visualsoft House Princes Wharf, Thornaby, Stockton On Tees, TS17 6QY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09073163
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Visualsoft House Princes Wharf
- Thornaby
- Stockton On Tees
- TS17 6QY
- United Kingdom Visualsoft House Princes Wharf, Thornaby, Stockton On Tees, TS17 6QY, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- JOHNSON, Timothy
- INNES, Neil
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-05 9 Jahre
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Fortran Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- VISUALSOFT HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-19
- Letzte Einreichung: 2021-06-05
-
VISUALSOFT HOLDINGS 4 LIMITED Firmenbeschreibung
- VISUALSOFT HOLDINGS 4 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09073163. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.06.2014 registriert. VISUALSOFT HOLDINGS 4 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VISUALSOFT HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Visualsoft House Princes Wharf erreicht werden.
Jetzt sichern VISUALSOFT HOLDINGS 4 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Visualsoft Holdings 4 Limited - Visualsoft House Princes Wharf, Thornaby, Stockton On Tees, TS17 6QY, Grossbritannien
- 2014-06-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VISUALSOFT HOLDINGS 4 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-01-06) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-01-06) - MA
-
second-filing-capital-allotment-shares (2021-01-09) - RP04SH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-06-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-18) - CS01
-
resolution (2021-07-05) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-21) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-11) - CS01
-
memorandum-articles (2020-11-24) - MA
-
resolution (2020-11-24) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-16) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-16) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-04-09) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-16) - TM01
-
capital-allotment-shares (2020-11-11) - SH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-10) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
change-sail-address-company-with-new-address (2019-10-08) - AD02
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-07-11) - RP04SH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-26) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-19) - CS01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2019-10-08) - AD03
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-03-28) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-04-05) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-04-03) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-12) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-06-22) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-24) - TM01
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-10-18) - SH02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-05) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-04-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-09-13) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-04-26) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-09-06) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-09-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-17) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-21) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-29) - AR01
-
resolution (2015-06-09) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-06-09) - SH01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-06-09) - SH10
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-06-05) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-07-09) - TM01
-
change-of-name-notice (2014-07-10) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2014-07-10) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-28) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-11) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-07-11) - AD01
-
capital-allotment-shares (2014-08-12) - SH01