-
QM RECOVERY LTD - Anfield Business Centre, 58 Breckfield Road South, Liverpool, L6 5DR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09065032
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Anfield Business Centre
- 58 Breckfield Road South
- Liverpool
- L6 5DR
- England Anfield Business Centre, 58 Breckfield Road South, Liverpool, L6 5DR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HAYES, Jessica Sandra Marie
- SMITH, Karen Ann
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-02 9 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Miss Jessica Sandra Marie Hayes
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-06
- Letzte Einreichung: 2021-03-23
-
QM RECOVERY LTD Firmenbeschreibung
- QM RECOVERY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09065032. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.06.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Anfield Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern QM RECOVERY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Qm Recovery Ltd - Anfield Business Centre, 58 Breckfield Road South, Liverpool, L6 5DR, Grossbritannien
- 2014-06-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QM RECOVERY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
resolution (2023-07-28) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-07-28) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-28) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
gazette-notice-compulsory (2022-07-05) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-08-09) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-26) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-22) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2020-10-27) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-10-28) - DISS40
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-27) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-11) - PSC07
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-07-13) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-12) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-07-06) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-06-04) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-25) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-25) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-20) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-20) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-19) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-19) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-03-01) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-01) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-06-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-14) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-06) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-06) - AP01
-
incorporation-company (2014-06-02) - NEWINC