-
ELITE LAW SOLICITORS LIMITED - Equity House, 57 Hill Avenue, Amersham, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09050473
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Equity House
- 57 Hill Avenue
- Amersham
- Buckinghamshire
- HP6 5BX
- England Equity House, 57 Hill Avenue, Amersham, Buckinghamshire, HP6 5BX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOWEY, Stephen Edmond
- MIR, Mohammed Shakeel
- MISTRI, John
- SCOZZI, James Alexander
- CLARKE, Victoria Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-21 10 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Mistri
- Mr James Alexander Scozzi
- Mr Stephen Edmond Howey
- Mr John Mistri
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-11-30
- Letzte Einreichung: 2022-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-03
- Letzte Einreichung: 2022-05-20
-
ELITE LAW SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- ELITE LAW SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09050473. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Equity House erreicht werden.
Jetzt sichern ELITE LAW SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Elite Law Solicitors Limited - Equity House, 57 Hill Avenue, Amersham, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2014-05-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ELITE LAW SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-28) - CS01
-
resolution (2022-07-05) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2022-07-05) - MA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-11-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-09) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-14) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-24) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-03) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-03) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-03) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-18) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-08) - MR01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-22) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-24) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-22) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-01) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-02) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-06) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-26) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-11-21) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-04-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-17) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-30) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-09-29) - RESOLUTIONS
-
legacy (2014-09-29) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2014-09-29) - SH19
-
legacy (2014-09-29) - SH20
-
capital-allotment-shares (2014-11-14) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-14) - AP01
-
incorporation-company (2014-05-21) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2014-11-20) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-06) - AD01