-
JUPITER VISUAL COMMUNICATIONS LIMITED - 1, Beauchamp Court, 10 Victors Way, Barnet, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09041508
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1
- Beauchamp Court
- 10 Victors Way
- Barnet
- Hertfordshire
- EN5 5TZ
- United Kingdom 1, Beauchamp Court, 10 Victors Way, Barnet, Hertfordshire, EN5 5TZ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- MOSS, Bennett Ingram Harley
- SNAITH, David John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-15 10 Jahre
- SIC/NACE
- 18129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr David John Snaith
- Mr Bennett Ingram Harley Moss
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-29
- Letzte Einreichung: 2020-03-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-29
- Letzte Einreichung: 2020-05-15
-
JUPITER VISUAL COMMUNICATIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- JUPITER VISUAL COMMUNICATIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09041508. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "18129" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 1 erreicht werden.
Jetzt sichern JUPITER VISUAL COMMUNICATIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jupiter Visual Communications Limited - 1, Beauchamp Court, 10 Victors Way, Barnet, Grossbritannien
- 2014-05-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JUPITER VISUAL COMMUNICATIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-21) - AA
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2020-07-20) - RP04CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-31) - PSC07
-
confirmation-statement (2020-05-28) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-06-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-16) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-12) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-12) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-26) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-18) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-29) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-06-06) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-29) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-20) - AD01
-
auditors-resignation-company (2018-08-14) - AUD
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-28) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-29) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-22) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-18) - AA01
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-08-30) - SH02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-08-12) - DISS40
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2017-08-29) - RP04AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-02-03) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-06) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-06) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC02
-
capital-allotment-shares (2017-08-10) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-10) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-04) - AD01
-
auditors-resignation-company (2016-04-25) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-01-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-02) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-25) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-05-16) - AA01
-
incorporation-company (2014-05-15) - NEWINC