-
HAYBRIDGE PARK LIMITED - 68 West Street, Warminster, BA12 8JW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09021119
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 68 West Street
- Warminster
- BA12 8JW
- England 68 West Street, Warminster, BA12 8JW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MOORE, Peter Arthur
- SCHROEDER, Patricia Mary
- Prokuristen
- SCHROEDER, Patricia Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-01 10 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- L A Moore Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- ST CUTHBERTS MILL ESTATES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-15
- Letzte Einreichung: 2024-05-01
-
HAYBRIDGE PARK LIMITED Firmenbeschreibung
- HAYBRIDGE PARK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09021119. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.05.2014 registriert. HAYBRIDGE PARK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ST CUTHBERTS MILL ESTATES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 68 West Street erreicht werden.
Jetzt sichern HAYBRIDGE PARK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Haybridge Park Limited - 68 West Street, Warminster, BA12 8JW, England, Grossbritannien
- 2014-05-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HAYBRIDGE PARK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-05-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-05-22) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-23) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-05-14) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-21) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-09) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-09) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-11-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-21) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-02-27) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-27) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-02-27) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-05-01) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2014-09-10) - CERTNM
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-08-29) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-11) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-08-11) - AP03
-
resolution (2014-08-06) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-06-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-06-11) - AP01