-
ATAG HEATING TECHNOLOGY UK LIMITED - Suite 177 80 Churchill Square Business Centre, Kings Hill, West Malling, ME19 4YU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09020540
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 177 80 Churchill Square Business Centre
- Kings Hill
- West Malling
- ME19 4YU
- England Suite 177 80 Churchill Square Business Centre, Kings Hill, West Malling, ME19 4YU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MCPHERSON, Wilma Geddes
- TREANOR, Julie Marie
- TREANOR, Kevin Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-01 10 Jahre
- SIC/NACE
- 46740
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Trade Heating Services Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-26
- Letzte Einreichung: 2024-05-12
-
ATAG HEATING TECHNOLOGY UK LIMITED Firmenbeschreibung
- ATAG HEATING TECHNOLOGY UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09020540. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46740" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite 177 80 Churchill Square Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern ATAG HEATING TECHNOLOGY UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Atag Heating Technology Uk Limited - Suite 177 80 Churchill Square Business Centre, Kings Hill, West Malling, ME19 4YU, Grossbritannien
- 2014-05-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ATAG HEATING TECHNOLOGY UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-26) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2023-07-05) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-12) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-05-12) - PSC05
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-06) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-04-06) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-30) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-13) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-13) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-13) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-01) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-07) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-10-06) - SH02
-
resolution (2016-10-06) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-06) - AR01
-
capital-cancellation-shares (2016-03-09) - SH06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-25) - AP01
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-03-30) - SH03
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-12-18) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2015-12-18) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-12-18) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-07) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-08) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-09-29) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-07-17) - SH01
-
incorporation-company (2014-05-01) - NEWINC