-
PETTITS LIMITED - Motivair House Crompton Court, Attwood Road, Burntwood, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09015987
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Motivair House Crompton Court
- Attwood Road
- Burntwood
- Staffordshire
- WS7 3GG
- England Motivair House Crompton Court, Attwood Road, Burntwood, Staffordshire, WS7 3GG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWN, Michael John
- LEACH, Julian Paul
- SOPHER, Jon Andrew Victor
- Prokuristen
- BROWN, Michael John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-29 10 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Julian Paul Leach
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-13
- Letzte Einreichung: 2023-04-29
-
PETTITS LIMITED Firmenbeschreibung
- PETTITS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09015987. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.04.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Motivair House Crompton Court erreicht werden.
Jetzt sichern PETTITS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pettits Limited - Motivair House Crompton Court, Attwood Road, Burntwood, Staffordshire, Grossbritannien
- 2014-04-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PETTITS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
capital-alter-shares-subdivision (2023-08-23) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-11-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-06-01) - AD01
-
resolution (2023-08-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-01-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-12-01) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
capital-allotment-shares (2021-06-14) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-29) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2020-05-15) - PSC06
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-05-08) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-27) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-22) - AA
-
capital-allotment-shares (2019-05-08) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-08) - CS01
-
resolution (2017-11-20) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-11-20) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-01-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-11-22) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-02-26) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-01-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-10-16) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-29) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-03-03) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-03-03) - SH02
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-10-29) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-28) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-28) - AP01
-
termination-director-company (2014-05-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-30) - AP01
-
incorporation-company (2014-04-29) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2014-04-30) - TM01