-
PHARMA START LIMITED - Suite 1 3rd Floor 11-12 St James's Square, London, SW1Y 4LB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09011133
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 1 3rd Floor 11-12 St James's Square
- London
- SW1Y 4LB Suite 1 3rd Floor 11-12 St James's Square, London, SW1Y 4LB UK
Management
- Geschäftsführung
- CARBONELL, John James Curdie
- DUFOUR, Justin Damian
- KAUFFMAN, Scott William
- WOODS, Michael
- Prokuristen
- VISTRA COSEC LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.04.2014
- Gelöscht am:
- 2018-01-09
- SIC/NACE
- 82990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-09
- Letzte Einreichung: 2021-04-25
-
PHARMA START LIMITED Firmenbeschreibung
- PHARMA START LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09011133. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.04.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite 1 3Rd Floor 11-12 St James's Square erreicht werden.
Jetzt sichern PHARMA START LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pharma Start Limited - Suite 1 3rd Floor 11-12 St James's Square, London, SW1Y 4LB, Grossbritannien
- 2014-04-25
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PHARMA START LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company (2019-07-01) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-27) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-26) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-25) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2019-06-25) - AP04
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-13) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-25) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-08-09) - PSC08
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-09) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-13) - AA
-
administrative-restoration-company (2018-07-13) - RT01
-
gazette-dissolved-compulsory (2018-01-09) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2017
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-08-12) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-11) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-03) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-14) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-09) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-04-25) - AA01
-
incorporation-company (2014-04-25) - NEWINC