-
REDX IMMUNOLOGY LIMITED - Block 33 Mereside, Alderley Park, Macclesfield, SK10 4TG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09000503
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Block 33 Mereside
- Alderley Park
- Macclesfield
- SK10 4TG
- England Block 33 Mereside, Alderley Park, Macclesfield, SK10 4TG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MEAD, James Robert, Dr
- ROSS, Iain Gladstone
- ANSON, Lisa Mary Whewell
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-16 10 Jahre
- SIC/NACE
- 72110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Redx Pharma Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- REDX METABOLIC LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2021-04-16
-
REDX IMMUNOLOGY LIMITED Firmenbeschreibung
- REDX IMMUNOLOGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09000503. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.04.2014 registriert. REDX IMMUNOLOGY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen REDX METABOLIC LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "72110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Block 33 Mereside erreicht werden.
Jetzt sichern REDX IMMUNOLOGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Redx Immunology Limited - Block 33 Mereside, Alderley Park, Macclesfield, SK10 4TG, Grossbritannien
- 2014-04-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REDX IMMUNOLOGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-08-07) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-27) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-10) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-24) - MR04
-
second-filing-notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-30) - RP04PSC02
-
resolution (2020-04-21) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-23) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-30) - MR01
-
memorandum-articles (2020-07-13) - MA
-
resolution (2020-07-13) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-06-02) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-10) - MR04
-
memorandum-articles (2020-04-07) - MA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-05) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-06-12) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-03-20) - AA
-
resolution (2019-07-02) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2019-07-02) - MA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-05) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-03-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-05-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-04) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-02-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-20) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-04-14) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-12-23) - CERTNM
-
incorporation-company (2014-04-16) - NEWINC