-
ESSENCE INTERNATIONAL SEARCH LIMITED - 2, South View, Collingham, Wetherby, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08993177
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2
- South View
- Collingham
- Wetherby
- LS22 5DF
- England 2, South View, Collingham, Wetherby, LS22 5DF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- THOMPSON, Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-11 10 Jahre
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Peter Thompson
- Mr Peter Thompson
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- THOMPSON MCHALE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-27
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-14
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
-
ESSENCE INTERNATIONAL SEARCH LIMITED Firmenbeschreibung
- ESSENCE INTERNATIONAL SEARCH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08993177. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.04.2014 registriert. ESSENCE INTERNATIONAL SEARCH LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THOMPSON MCHALE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 2 erreicht werden.
Jetzt sichern ESSENCE INTERNATIONAL SEARCH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Essence International Search Limited - 2, South View, Collingham, Wetherby, Grossbritannien
- 2014-04-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ESSENCE INTERNATIONAL SEARCH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-02) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-11) - PSC07
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-06-11) - PSC09
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-24) - AP01
-
resolution (2018-05-17) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2018-05-17) - CONNOT
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-15) - CS01
-
resolution (2016-05-19) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2016-05-19) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2016-05-05) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2016-05-05) - CONNOT
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-10) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-11) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-12-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-09-19) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-19) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-19) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-09-16) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-23) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-16) - AD01
-
incorporation-company (2014-04-11) - NEWINC