-
ATLAS EMAR LTD - 1 Bell Court, Leapale Lane, Guildford, GU1 4LY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08972421
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Bell Court
- Leapale Lane
- Guildford
- GU1 4LY
- England 1 Bell Court, Leapale Lane, Guildford, GU1 4LY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COLES, Andrew
- PAPWORTH, Jonathan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-02 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Invatech Health (Atlas) Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- INVATECH HEALTH LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-02-29
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-16
- Letzte Einreichung: 2023-04-02
-
ATLAS EMAR LTD Firmenbeschreibung
- ATLAS EMAR LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08972421. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.04.2014 registriert. ATLAS EMAR LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen INVATECH HEALTH LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 1 Bell Court erreicht werden.
Jetzt sichern ATLAS EMAR LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Atlas Emar Ltd - 1 Bell Court, Leapale Lane, Guildford, GU1 4LY, Grossbritannien
- 2014-04-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ATLAS EMAR LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-10-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-15) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2023-07-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-11-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-11-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-05-18) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-05-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-09) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-05-19) - AP01
-
memorandum-articles (2022-10-19) - MA
-
resolution (2022-10-19) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-05-10) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-10-11) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-08-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-23) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-23) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-04-10) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-09-11) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2019-09-11) - CONNOT
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-09-05) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-02) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-29) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-29) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2019-08-29) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-01-31) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-09-05) - PSC02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2018-09-17) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-03) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-26) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-09) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-12-07) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-09-18) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-12) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-08-28) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-15) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2014-07-16) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2014-07-16) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-11) - AD01
-
incorporation-company (2014-04-02) - NEWINC