-
CLEARVIEW ENDOSCOPY LIMITED - 4 Walls Yard Riverside Industrial Estate, South Street, Rochford, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08972188
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Walls Yard Riverside Industrial Estate
- South Street
- Rochford
- Essex
- SS4 1GR 4 Walls Yard Riverside Industrial Estate, South Street, Rochford, Essex, SS4 1GR UK
Management
- Geschäftsführung
- LAVELLE, Keith Edward
- LIKELY, Darren John
- PRICE, Amanda
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-02 10 Jahre
- SIC/NACE
- 33190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Dawn Van Win
- -
- -
- Clearview Medtech Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-07-31
- Letzte Einreichung: 2022-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-04-16
- Letzte Einreichung: 2024-04-02
-
CLEARVIEW ENDOSCOPY LIMITED Firmenbeschreibung
- CLEARVIEW ENDOSCOPY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08972188. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.04.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33190" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2015 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4 Walls Yard Riverside Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern CLEARVIEW ENDOSCOPY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Clearview Endoscopy Limited - 4 Walls Yard Riverside Industrial Estate, South Street, Rochford, Essex, Grossbritannien
- 2014-04-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CLEARVIEW ENDOSCOPY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-updates (2024-04-10) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2024-04-10) - PSC05
keyboard_arrow_right 2023
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-05-31) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-07-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-07-05) - AP01
-
resolution (2023-06-28) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2023-06-16) - MA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-06-06) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-06-06) - PSC07
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-06-01) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-10-20) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-03) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-01-11) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-07-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-05-10) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-10) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-28) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-28) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-22) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-07-28) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-08) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-16) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-24) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-10) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-10-24) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-12) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-03) - MR01
-
capital-cancellation-shares (2017-02-13) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-02-13) - SH03
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-13) - TM01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-05-28) - RP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-17) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-04-10) - SH01
-
incorporation-company (2014-04-02) - NEWINC