-
NF TECHFLEET (UK) LIMITED - Barons Court, 22 The Avenue, Egham, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08960974
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Barons Court
- 22 The Avenue
- Egham
- Surrey
- TW20 9AB
- England Barons Court, 22 The Avenue, Egham, Surrey, TW20 9AB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MCGLONE, Declan Martin
- YOUNG, Simon James
- Prokuristen
- BIGG, Steven Alan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.03.2014
- Gelöscht am:
- 2021-11-30
- SIC/NACE
- 64910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Frank Gelf
- Mr Juergen Mossakowski
- Mrs Susanne Gelf-Kapler
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- AGHOCO 1209 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-09
- Letzte Einreichung: 2021-03-26
-
NF TECHFLEET (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- NF TECHFLEET (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08960974. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.03.2014 registriert. NF TECHFLEET (UK) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AGHOCO 1209 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64910" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Barons Court erreicht werden.
Jetzt sichern NF TECHFLEET (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nf Techfleet (Uk) Limited - Barons Court, 22 The Avenue, Egham, Surrey, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NF TECHFLEET (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-06-21) - AA
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-11-30) - GAZ2(A)
-
gazette-notice-voluntary (2021-09-14) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-24) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-08-20) - MR04
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-09-01) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-12) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-03-05) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-12) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-29) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-04-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-11) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-05-11) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-05-11) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-25) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-03-26) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2014-04-11) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name (2014-06-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-06-10) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-10) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-10) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-06-23) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-23) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-06-10) - AA01