-
ALLT CORALAN HYDRO LIMITED - C/O Turcan Connell, 12 Stanhope Gate, London, W1K 1AW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08945627
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Turcan Connell
- 12 Stanhope Gate
- London
- W1K 1AW
- England C/O Turcan Connell, 12 Stanhope Gate, London, W1K 1AW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LAU, Ming Wai
- WONG, Carmen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-18 10 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- -
- Profound Uk Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ALLT CORALAN 2014 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-06
- Letzte Einreichung: 2023-09-22
-
ALLT CORALAN HYDRO LIMITED Firmenbeschreibung
- ALLT CORALAN HYDRO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08945627. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.03.2014 registriert. ALLT CORALAN HYDRO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ALLT CORALAN 2014 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Turcan Connell erreicht werden.
Jetzt sichern ALLT CORALAN HYDRO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Allt Coralan Hydro Limited - C/O Turcan Connell, 12 Stanhope Gate, London, W1K 1AW, Grossbritannien
- 2014-03-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALLT CORALAN HYDRO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-10-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-10) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-05-15) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2022-12-16) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-09-30) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-27) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-09-30) - PSC07
keyboard_arrow_right 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-04) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-08) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-04) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-09) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-12) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-12) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-03-12) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-12) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-19) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-09) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-19) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-14) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-14) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-04) - PSC04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-04-02) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-12-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2018-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-of-name-notice (2017-06-22) - CONNOT
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-16) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-05-15) - AA01
-
resolution (2017-06-22) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-22) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-11-17) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-17) - AD01
-
resolution (2014-07-07) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-18) - MR01
-
incorporation-company (2014-03-18) - NEWINC