-
FERN PROPERTY LTD - Ency Associates Printware Court, Cumberland Business Centre, Portsmouth, Hants, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08939267
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ency Associates Printware Court
- Cumberland Business Centre
- Portsmouth
- Hants
- PO5 1DS Ency Associates Printware Court, Cumberland Business Centre, Portsmouth, Hants, PO5 1DS UK
Management
- Geschäftsführung
- PARKER, Jason Aaron
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-14 10 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Soraya Parker
- -
- Mr Jason Aaron Parker
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-27
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-28
- Letzte Einreichung: 2021-03-14
-
FERN PROPERTY LTD Firmenbeschreibung
- FERN PROPERTY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08939267. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2015 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Ency Associates Printware Court erreicht werden.
Jetzt sichern FERN PROPERTY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fern Property Ltd - Ency Associates Printware Court, Cumberland Business Centre, Portsmouth, Hants, Grossbritannien
- 2014-03-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FERN PROPERTY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-09-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-16) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-09-02) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-02) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-02) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-21) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-05) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-05) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-21) - AA01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-14) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-14) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-15) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-15) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-15) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-18) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-05-16) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-15) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-18) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-15) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-12-21) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-14) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-12-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-11) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-10) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-14) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-17) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-17) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-07) - TM01
-
incorporation-company (2014-03-14) - NEWINC