-
BRIDGWATER RESOURCE RECOVERY LIMITED - Unit G1 Ash Tree Court, Nottingham Business Park, Nottingham, NG8 6PY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08932414
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit G1 Ash Tree Court
- Nottingham Business Park
- Nottingham
- NG8 6PY
- England Unit G1 Ash Tree Court, Nottingham Business Park, Nottingham, NG8 6PY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ARCHER, Egan Douglas
- GORDON, Stuart John
- WAKEFIELD, Nathan John
- Prokuristen
- DUGGAN, Michael George
- ENEIGHO, Lemnwie Ajiteh
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-11 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Andrew Jonathan Olie
- Michele Olie
- -
- Bridgwater Energy Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-15
- Letzte Einreichung: 2023-02-01
-
BRIDGWATER RESOURCE RECOVERY LIMITED Firmenbeschreibung
- BRIDGWATER RESOURCE RECOVERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08932414. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit G1 Ash Tree Court erreicht werden.
Jetzt sichern BRIDGWATER RESOURCE RECOVERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bridgwater Resource Recovery Limited - Unit G1 Ash Tree Court, Nottingham Business Park, Nottingham, NG8 6PY, Grossbritannien
- 2014-03-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRIDGWATER RESOURCE RECOVERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-01-12) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-07) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-08) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-24) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-11) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-06-07) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-12-08) - TM02
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-05-06) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-01-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-22) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-01-30) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-10) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-12-13) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-05) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-05) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-05) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-05) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-05) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-03) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-02) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-12-05) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
-
resolution (2017-02-10) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-02-10) - SH02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-07-20) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-03-11) - NEWINC