-
BOSLEY PARK LTD - The Pinnacle 3rd Floor, 73 King Street, Manchester, M2 4NG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08925641
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Pinnacle 3rd Floor
- 73 King Street
- Manchester
- M2 4NG The Pinnacle 3rd Floor, 73 King Street, Manchester, M2 4NG UK
Management
- Geschäftsführung
- AITKEN, Douglas William
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-06 10 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Douglas William Aitken
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-03-29
- Letzte Einreichung: 2017-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-20
- Letzte Einreichung: 2018-03-06
-
BOSLEY PARK LTD Firmenbeschreibung
- BOSLEY PARK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08925641. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Pinnacle 3Rd Floor erreicht werden.
Jetzt sichern BOSLEY PARK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bosley Park Ltd - The Pinnacle 3rd Floor, 73 King Street, Manchester, M2 4NG, Grossbritannien
- 2014-03-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BOSLEY PARK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-24) - 600
-
resolution (2019-07-24) - RESOLUTIONS
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-07-06) - DISS16(SOAS)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-13) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-28) - GAZ1
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-07-24) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-05-24) - TM02
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-15) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-11-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-05) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-09-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-07-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
memorandum-articles (2014-12-19) - MA
-
resolution (2014-12-19) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-04-11) - AA01
-
incorporation-company (2014-03-06) - NEWINC