-
MONDI UK CONSUMER PACKAGING HOLDING 2 LTD - Building 1,, 1st Floor Aviator Park, Station Road, Addlestone, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08925262
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Building 1,
- 1st Floor Aviator Park
- Station Road
- Addlestone
- Surrey
- KT15 2PG
- United Kingdom Building 1,, 1st Floor Aviator Park, Station Road, Addlestone, Surrey, KT15 2PG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DRAKES, Sian
- LEEB, Juergen
- Prokuristen
- BRAGG, Ian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.03.2014
- Gelöscht am:
- 2021-10-26
- SIC/NACE
- 22220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mondi Investments Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ENACT NEWCO 4 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-17
- Letzte Einreichung: 2020-03-06
-
MONDI UK CONSUMER PACKAGING HOLDING 2 LTD Firmenbeschreibung
- MONDI UK CONSUMER PACKAGING HOLDING 2 LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08925262. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.03.2014 registriert. MONDI UK CONSUMER PACKAGING HOLDING 2 LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ENACT NEWCO 4 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22220" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Building 1 erreicht werden.
Jetzt sichern MONDI UK CONSUMER PACKAGING HOLDING 2 LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mondi Uk Consumer Packaging Holding 2 Ltd - Building 1,, 1st Floor Aviator Park, Station Road, Addlestone, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MONDI UK CONSUMER PACKAGING HOLDING 2 LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-30) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-14) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-08-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-08-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-07) - TM01
-
resolution (2019-12-17) - RESOLUTIONS
-
legacy (2019-12-17) - CAP-SS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-07) - AP01
-
legacy (2019-12-17) - SH20
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-19) - PSC02
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-12-17) - SH19
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-02-13) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-08-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-20) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-12-04) - SH01
-
resolution (2017-12-01) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
-
resolution (2017-02-07) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-22) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-03-30) - RP04
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-12-22) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-05-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-02) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-02-20) - AA01
-
resolution (2015-01-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-03-06) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-13) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-17) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-19) - AP01