-
CENTRIC ENGINEERING SUPPLIES LIMITED - Unit 9 Curriers Close, Charter Avenue Industrial Estate, Coventry, CV4 8AW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08923565
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 9 Curriers Close
- Charter Avenue Industrial Estate
- Coventry
- CV4 8AW
- England Unit 9 Curriers Close, Charter Avenue Industrial Estate, Coventry, CV4 8AW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GOWER, Paul Stanley
- GOWER, Susan Carol
- WESTMAN, Sondra Jane
- WESTMAN, Steven Joseph
- EVANS, Helen Margaret
- EVANS, Peter George
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-05 10 Jahre
- SIC/NACE
- 25620
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Stanley Gower
- Mrs Susan Carol Gower
- Mr Steven Joseph Westman
- Mrs Sondra Jane Westman
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Ehemalige Namen
- HAWKRIDGE SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-14
- Letzte Einreichung: 2023-02-28
-
CENTRIC ENGINEERING SUPPLIES LIMITED Firmenbeschreibung
- CENTRIC ENGINEERING SUPPLIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08923565. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.03.2014 registriert. CENTRIC ENGINEERING SUPPLIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HAWKRIDGE SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25620" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 9 Curriers Close erreicht werden.
Jetzt sichern CENTRIC ENGINEERING SUPPLIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Centric Engineering Supplies Limited - Unit 9 Curriers Close, Charter Avenue Industrial Estate, Coventry, CV4 8AW, Grossbritannien
- 2014-03-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CENTRIC ENGINEERING SUPPLIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-notice-compulsory (2024-05-21) - GAZ1
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-05-28) - DS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-30) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-04-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2022-02-22) - SH10
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2022-02-25) - SH10
-
confirmation-statement-with-updates (2022-02-28) - CS01
-
resolution (2022-03-03) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-03-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-18) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-30) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-25) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-15) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-04-10) - SH01
-
resolution (2015-04-10) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2015-03-18) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-03-18) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-10) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-03-09) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-26) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-26) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-03-05) - NEWINC