-
GREEN WAVE TECHNOLOGIES LIMITED - 3 Park Court, Pyrford Road, West Byfleet, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08923345
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Park Court
- Pyrford Road
- West Byfleet
- Surrey
- KT14 6SD
- England 3 Park Court, Pyrford Road, West Byfleet, Surrey, KT14 6SD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- YAQUB, Anna, Dr
- DAY, Tony Martin
- GEOGHEGAN, Bernard
- HEWKIN, Peter Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-05 10 Jahre
- SIC/NACE
- 85590
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Georg Katcz
- Prof Dr Michael Stark
- Ms Anna Yaqub
- -
- -
- Mr Peter Charles Hewkin
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FUFI ASSOCIATES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-19
- Letzte Einreichung: 2021-03-05
-
GREEN WAVE TECHNOLOGIES LIMITED Firmenbeschreibung
- GREEN WAVE TECHNOLOGIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08923345. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.03.2014 registriert. GREEN WAVE TECHNOLOGIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FUFI ASSOCIATES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85590" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3 Park Court erreicht werden.
Jetzt sichern GREEN WAVE TECHNOLOGIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Green Wave Technologies Limited - 3 Park Court, Pyrford Road, West Byfleet, Surrey, Grossbritannien
- 2014-03-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREEN WAVE TECHNOLOGIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-04) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-23) - AP01
-
capital-allotment-shares (2021-01-23) - SH01
-
capital-allotment-shares (2021-01-19) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-01-06) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-04-13) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-13) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-08) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-04) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-05) - CS01
-
resolution (2020-12-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-14) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-19) - AA
-
resolution (2019-06-17) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-06-14) - TM02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-14) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-14) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-29) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-28) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-28) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-04) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-19) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-04-09) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-07) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2016-02-09) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-26) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2015-02-26) - CH04
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-03-05) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-20) - TM01