-
GABBS SOLICITORS LIMITED - 14 Broad Street, Hereford, Herefordshire, HR4 9AP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08920546
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14 Broad Street
- Hereford
- Herefordshire
- HR4 9AP 14 Broad Street, Hereford, Herefordshire, HR4 9AP UK
Management
- Geschäftsführung
- LEE, James Joseph
- THEOBALD, Carolyn Margaret
- TREE, Melanie Ann
- WILDING, Jeremy John Edwin
- Prokuristen
- WILDING, Jeremy John Edwin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-03 10 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Jeremy John Edwin Wilding
- Mrs Melanie Ann Tree
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-14
- Letzte Einreichung: 2020-03-03
-
GABBS SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- GABBS SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08920546. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 14 Broad Street erreicht werden.
Jetzt sichern GABBS SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gabbs Solicitors Limited - 14 Broad Street, Hereford, Herefordshire, HR4 9AP, Grossbritannien
- 2014-03-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GABBS SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-02-04) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-10) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-14) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-29) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-16) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-16) - PSC07
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-03-05) - CH03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-28) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-28) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-10) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-03-03) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-28) - MR01
-
incorporation-company (2014-03-03) - NEWINC