-
SETH LOVIS & CO SOLICITORS LIMITED - 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08913382
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25 Moorgate
- London
- EC2R 6AY 25 Moorgate, London, EC2R 6AY UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Nicholas Guy
- JACKIEWICZ, John
- NICHOLS, Warren James
- TYLER, Jonathan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-26 10 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Seth Lovis
- Mr Seth Lovis
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- administration
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-12
- Letzte Einreichung: 2018-02-26
-
SETH LOVIS & CO SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- SETH LOVIS & CO SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08913382. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.02.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 25 Moorgate erreicht werden.
Jetzt sichern SETH LOVIS & CO SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Seth Lovis & Co Solicitors Limited - 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Grossbritannien
- 2014-02-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SETH LOVIS & CO SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-10-24) - AM10
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-17) - TM01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-a-replacement-or-additional-administrator (2020-07-07) - AM11
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2020-02-20) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-05-19) - AM10
-
liquidation-in-administration-removal-of-administrator-from-office (2020-05-22) - AM16
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-22) - TM01
-
liquidation-in-administration-proposals (2019-05-21) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-27) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2019-03-26) - AM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-02-18) - AA
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-10-28) - AM10
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-07-22) - TM02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-26) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-03) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-12) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-10) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-25) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-18) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-03-18) - CH03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-16) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-12) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-26) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-27) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-11-07) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-10) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-09) - AD01
-
incorporation-company (2014-02-26) - NEWINC